Concurrent Meeting of the Oakland 
Redevelopment Agency/City Council
City of Oakland
Online Meeting Agenda
Office of the City Clerk
Oakland City Hall
Frank HOgawa Plaza
Oakland, California 
94612
Ceda Floyd, City Clerk
Oakland City Hall, Frank HOgawa Plaza, Oakland, California, 94612
 
City of Oakland Website:  http://www.oaklandnet.com
Oakland City Hall, 3rd Floor
6:00 PM
Tuesday, September 16, 2003
 
 
Pledge of Allegiance
1
Roll Call ORA & Council
COUNCIL MEMBERS; Jane Brunner, Dist1; Danny Wan, Dist2; Vice Mayor Nancy Nadel, 
Dist3; Jean Quan, Dist4; Desley Brooks, Dist6; Larry Reid, Dist7; Henry Chang, At-Large, 
and President Ignacio De La Fuente, Dist5
2
Open Forum Citizens Comments 
(Time Available15 minutes)
3
Modifications to the Consent Calendar, and requests from Councilmember(sto pull an item 
from the Consent Calendar, shall be scheduled for the next-succeeding City Council meeting 
as a "non-consentitem.
4
Motion for 'Members' Requests for Reconsideration' of an Action taken at  the preceding 
Council Meeting, shall be scheduled for the next-succeeding City Council meeting as a "non-
consentitem.  (Motion Maker must have voted on "prevailing side")
5
Requests from Councilmember(sto schedule an Action Item considered by Committee but 
not forwarded to Council, shall be scheduled for the next-succeeding City Council meeting as 
"non-consentitem.
6
Approval of the Draft Minutes from the Concurrent Meeting of the Oakland Redevelopment 
Agency/City Council held on July 292003
7
8.  Presentation of Ceremonial Matters
Subject:     Viola Gonzales
From:          Mayor Brown
Recommendation:  Presentation of a Proclamation acknowledging service to 
the Oakland Unified School District By Mayoral School Board Appointee Viola 
Gonzales
8.1
9.  Council Acknowledgements / Announcements
10. CONSENT CALENDAR (CC) ITEMS:
The following Consent Calendar items are considered to be routine and will be 
acted upon by one motion of the City Council, unless a member of the public or 
a Councilmember requests the opportunity to speak on an item noticed.
Subject:     Declaration of a Local Emergency due to AIDS epidemic
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution renewing and continuing the City 
Council's Declaration of a Local Emergency due to the existence of a critical 
public health crisis with regard to the AIDS epidemic
10.1
10.1CC 9-30-03.pdf,
78038 CMS.pdf,
78068 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Medical Cannabis health emergency
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution renewing the City Council's Declaration 
of a local public health emergency with respect to safe, affordable access to 
Medical Cannabis in the City of Oakland
10.2
10.2CC 9-30-03.pdf,
10.2CC.pdf,
78039 CMS.pdf,
78069 CMS.pdf,
78111.pdf
Attachments:
Subject:     Margaret Russell Oakland Museum of California Foundation
From:          Office of the Mayor
Recommendations:  Adopt a Resolution appointing Margaret MRussell as a 
member of the Oakland Museum of California Foundation
10.3
78040 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Gloria Cox Health and Human Services Commission
From:          Office of the Mayor
Recommendation:  Adopt a Resolution appointing Gloria Cox Crowell as a 
member of the Health and Human Services Commission
10.4
78041 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Benjamin Scott Budget Advisory Committee
From:     Office of Mayor
Recommendation:  Adopt a Resolution appointing Benjamin Scott as a 
member of the Budget Advisory Committee
10.5
78042 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Gwen McDonald and Marcus Clark Civil Service Board
From:          Office of the Mayor
Recommendation:  Adopt a Resolution appointing Gwen McDonald and re-
appointing Marcus Clark as members of the Civil Service Board
10.6
78043 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Hillery Bolt Trippe and Jean Rubsamen Housing,
          Residential Rent and Relocation Board
From:          Office of the Mayor
Recommendation:  Adopt a Resolution appointing Hillery Bolt Trippe and Jean 
Rubsamen as members of the Housing, Residential Rent, and Relocation 
Board
10.7
20 9-30-03.pdf
Attachments:
Subject:          Alex Pedersen
From:          Councilmember Wan
RecommendationAdopt a Resolution appointing Alex Pedersen as 
Councilmember Wan's District Two Adult Representative member of the 
Children's Fund Planning and Oversight Committee
10.8
78044 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Benjamin Fay Budget Advisory Committee
From:     Councilmember Chang
Recommendation:     Adopt a Resolution appointing Benjamin Fay as At-Large 
Representative as a member of the Budget Advisory Committee
10.9
78045 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Marcia McClean Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Marcia McClean vCity of 
Oakland, et al., Alameda County Superior Court Case No2001-023537, our 
file no21563, in the amount of 
$7,500.00 (Public Works Agency)
10.10
78046 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Conco Cement Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Conco Cement, in the amount 
of $10,610.64, as a result of property damage sustained when the driver of a 
City of Oakland vehicle rear-ended the vehicle driven by Ashley NWatson (
Oakland Police Department)
10.11
78047 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Antonous Boykin Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the claim of Antonous Boykin in the amount 
of $5,600.00 as a result of a vehicle collision involving a City vehicle (Oakland 
Police Department)
10.12
78048 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Jermain Jenkins, Jada Powell etal. - Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Jermain Jenkins, Jada Powell 
as the guardian ad litem for Jatasia Jenkins, Jermain Jenkins Jr., Earsey 
Jenkins, and their attorney of record Craig MBoeger, Esqin the amount of 
twenty thousand seven hundred fifty dollars and no cents ($20,750.00), as a 
result of bodily injuries sustained when a City employee driving a City vehicle 
failed to stop at the red signal light and collided with the vehicle driven by 
Jermain Jenkins (Public Works Agency)
10.13
78049 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Kereem Thurston Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Kereem Thurston vCity of 
Oakland, etal., United States District Court Case NoC-01 3839 WDB, our file 
no21395, in the amount of $15,000.00; This case involves a claim of use of 
excessive force (Oakland Police Department-Alleged Civil Rights Violation)
10.14 
CC
10.7ACC.pdf,
78116.pdf
Attachments:
Subject:     Chesarae Fletcher and Jeffrey Fletcher Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Chesarae Fletcher and Jeffrey 
Fletcher vCity of Oakland, Superior Court, County of Alameda, Case No
2002041360 in the amount of 
$8,500.00 (Public Works Agency)
10.15 
CC
78050 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Daniel McClosky Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Daniel McClosky vCity of 
Oakland, Superior Court, County of Alameda, Case No2002065331 in the 
amount of $10,000.00 (Public Works Agency)
10.16
78051 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Progressive Insurance Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the claim of Progressive Insurance as 
Subrogee of Beatrice Pecot in the amount of $14,063.06 as a result of a 
vehicle collision involving a City vehicle
(Oakland Police Department)
10.17
78052 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Kerry Salisbury Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Kerry Salisbury vCity of 
Oakland, Alameda County Superior Court No2002-040857, our file no21795
a defamation and breach of contract case in the amount of $9,000.00; Mr
Salisbury, a former employee, claims that comments made after his departure 
in June 2001 were defamatory and violated a written agreement with the City (
Life Enrichment Agency)
10.18 
CC
78053 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Jackie Stewart Settlement Agreement
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing and directing the City 
Attorney to compromise and settle the case of Jackie Stewart vCity of 
Oakland, Alameda County Superior Court No2001-035552our file no21404
a personal injury case in the amount of $8,500.00; MsStewart tripped and fell 
in a pothole on Lincoln Way (Public Works Agency)
10.19 
CC
78054 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Oakland's Stolen Gun Ordinance
From:          Oakland Police Department
RecommendationApprove the Final Passage (Second Readingof an 
Ordinance amending Sections 9.36.131 and 9.36.141 of the Oakland Municipal 
Code providing a 60 day reporting period during which the owner or person in 
possession of a firearm is required to report the theft or loss of a firearm 
occurring between August 11992 and July 302002
10.20 
CC
12529 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Reading] was approved on July 29, 2003; Vote Count 8 Ayes)
Subject:     Paul Wang Enterprises
From:          Community and Economic Development Agency
RecommendationApprove recommendations for the following legislation:
 
Approve the Final Passage (Second Readingof an Ordinance rescinding 
Ordinance 12223 C.M.S., and transferring ownership of six City-owned 
properties at 2824 82nd Avenue, 8207 Golf Links Road, 8251-8329 Golf Links 
Road, 8379 Golf Links Road, 8477 Golf Links Road, and 8395 Golf Links Road 
to the Redevelopment Agency of the City of Oakland; and
10.21 
CC
12530 CMS.pdf
Attachments:
2Approve the Final Passage (Second Readingof Ordinance rescinding 
Ordinance 12217 C.M.Sand authorizing the negotiation and execution of a 
Disposition and Development Agreement with Paul Wang Enterprises, to 
provide for the sale and development of nine City-owned properties at 938 46th 
Street, 62nd Street at Marshall Street, 1027 62nd Street, 1311 Campbell 
Street, 820 Peralta Street, 901 70th Avenue, 1088 71st Avenue, 3214 
Courtland Avenue, and 2849 Kitchener Court/4291 Wilshire Boulevard, with six 
units of affordable housing and six units of market-rate housing
-
12531 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Readingwas approved on July 292003; Vote Count Ayes, 
Abstain Brooks)
Subject:          Oakland Base Reuse Authority Joint Powers Agreement
From:          Community and Economic Development Agency
RecommendationApprove Final Passage (Second Readingof an Ordinance 
altering the Port area boundary to include and exclude various specified 
parcels at and adjacent to the former Oakland Army Base
10.22 
CC
12532 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Reading] was approved on July 29, 2003; Vote Count 8 Ayes)
Subject:          Commercial Business Security Devices
From:          Community and Economic Development Agency
Recommendation:  Approve the Final Passage (Second Readingof an 
Ordinance amending the Oakland Planning Code to prohibit the use of barbed 
wire and razor wire in the Commercial and S-1, S-2, S-3, and S-15 Zoning 
Districts; establish fence height limits in these districts; and relocate fence 
regulations within the Code
10.23 
CC
12533 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Reading] was approved on July 29, 2003; Vote Count 8 Ayes)
Subject:          9507 Edes Avenue Disposition and Development
From:          Community and Economic Development Agency
RecommendationApprove the Final Passage (Second Readingof an 
Ordinance rescinding Ordinance No12219 C.M.S., and authorizing the sale of 
the City-owned property at 9507 Edes Avenue to the Redevelopment Agency 
at its fair market value;  and
10.24 
CC
12534 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Reading] was approved on July 29, 2003; Vote Count 8 Ayes)
Subject:     Palo Seco Substation Expansion
From:          Community and Economic Development Agency
RecommendationApprove the Final Passage (Second Readingof an 
Ordinance authorizing the City Manager to enter into a purchase and sales 
agreement in the amount of six thousand three hundred dollars ($6,300.00
with Pacific Gas and Electric Company to grant a permanent easement for 
expansion of Palo Seco Substation to provide emergency back up power to the 
Oakland Hills over the City owned property located on Monterey Blvd. (APN
0291330 034 00)
10.25 
CC
12535 CMS.pdf
Attachments:
(Introduction [First Reading] was approved on July 29, 2003; Vote Count 8 Ayes)
COMMENCING AT 7:00 P.M. OR AS SOON AS REASONABLY PRACTICAL THEREAFTER:
An oral report from the Agency Counsel City Attorney of final decisions made during Closed 
Session
11
A disclosure of non-confidential Closed Session Discussion pursuant to Section 15 to the 
Sunshine Ordinance
12
Reconsideration of Ordinances pursuant to Charter Section 216
13
Consideration of items with statutory Public Hearing Requirements:
Subject:     Delinquent Real Property Transfer Taxes Public Hearing
From:          Finance and Management Agency
RecommendationConduct a Public Hearing regarding the assessment of liens 
for Delinquent Real Property Transfer Taxes and upon conclusion adopt one of 
the following Resolutions:
 
1)     Adopt a Resolution accepting and confirming reports of the Interim City 
Manager on the costs incurred by the City of Oakland for delinquent real 
property transfer taxes, and confirming the recordation of liens, administrative 
charges, and assessment  charges, as necessary, pursuant to Chapter 4.20 of 
the Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and assessment 
charges to be turned over to the County Tax Collector for collection; or
14
78055 CMS.pdf
Attachments:
2)     Adopt a Resolution overruling protests and objections, and accepting and 
confirming reports of the Interim City Manager on the costs incurred by the City 
of Oakland for delinquent real property transfer taxes, and authorizing the 
recordation of liens, administrative charges as necessary pursuant to Chapter 
4.20 of the Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and 
assessment charges to be turned over to the County Tax Collector for 
collection; or
 
3)     Adopt a Resolution continuing hearing on reports of the Interim City 
Manager on the delinquent real property transfer taxes and confirming the 
recordation of liens, admininstrative charges, and assessment charges as 
necessary pursuant to Chapter 4.20 of the Oakland Municipal Code, and 
directing the notice of lien and assessment charges to be turned over to the 
Alameda County Tax Collector for collection
Subject:     Delinquent Business Taxes Public Hearing 
From:          Finance and Management Agency
RecommendationConduct a Public Hearing regarding the assessment of liens 
for Delinquent Business Tax and upon conclusion adopt one of the following 
Resolutions:
 
1)     Adopt a Resolution accepting and confirming reports of the Interim City 
Manager on the costs incurred by the City of Oakland for delinquent business 
taxes and confirming the recordation of liens, administrative charges and 
assessment charges as necessary -  pursuant to Title 5, Chapter 5.04 of the 
Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and assessment 
charges to be turned over to the County for collection; or
-
15
78056 CMS.pdf
Attachments:
2)      Adopt a Resolution overruling protests and accepting and confirming 
reports of the Interim City Manager on the delinquent business taxes, and 
confirming the recordation of liens, administrative charges, and assessment 
charges as necessary, pursuant to Title 5, Chapter 5.04 of the Oakland 
Municipal Code, and directing the notice of lien and assessment charges to be 
turned over to the County Tax Collector for collection; or
 
3)      Adopt a Resolution continuing hearing on reports of the Interim City 
Manager on the delinquent business taxes, and confirming the recordation of 
liens, administrative charges and assessment charges, as necessary, pursuant 
to Title 5, Chapter 5.04 of the Oakland Municipal Code
Subject:     Delinquent Mandatory Garbage Fees Public Hearing
From:          Finance and Management Agency
RecommendationConduct a Public Hearing regarding Delinquent Mandatory 
Garbage Fees for April June 2003, quarterly accounts and January March 
2003 monthly accounts and upon conclusion adopt one of the following 
Resolutions:
 
1)     Adopt a Resolution accepting and confirming reports of the Interim City 
Manager on the costs incurred by the City of Oakland for delinquent garbage 
service fees, and confirming the recordation of liens, administrative charges, 
and assessment charges, as necessary, pursuant to Chapter 8.28 of the 
Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and assessment 
charges to be turned over to the County Tax Collector for collection; or
-
16
78057 CMS.pdf
Attachments:
2)     Adopt a Resolution overruling protests and objections, and accepting and 
confirming reports of the Interim City Manager on the costs incurred by the City 
of Oakland for delinquent garbage service fees, and authorizing the 
recordation of liens, administrative charges, as necessary, pursuant to Chapter 
8.28 of the Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and 
assessment charges to be turned over to the County Tax Collector for 
collection; or
 
3)      Adopt a Resolution continuing hearing on reports of the Interim City 
Manager on the delinquent garbage service fees, and confirming the 
recordation of liens, administrative charges, and assessment charges, as 
necessary, pursuant to Chapter 8.28 of the Oakland Municipal Code, and 
directing the notice of lien and assessment charges to be turned over to the 
Alameda County Tax Collector for collection
Subject:     Delinquent Transient Occupancy Taxes Public Hearing
From:          Finance and Management Agency
RecommendationConduct a Public Hearing regarding the assessment of liens 
for Delinquent Transient Occupancy Taxes and upon conclusion adopt one of 
the following Resolutions:
 
1)     Adopt a Resolution accepting and confirming reports of the Interim City 
Manager on the costs incurred by the City of Oakland for Delinquent Transient 
Occupancy Taxes and confirming the recordation of liens, administrative 
charges, and assessment charges as necessary pursuant to Title 4, Chapter 
4.24 of the Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and 
assessment charges to be turned over to the County for collection; or
17
78058 CMS.pdf
Attachments:
2)     Adopt a Resolution overruling protests and accepting and confirming 
reports of the Interim City Manager on the Delinquent Transient Occupancy 
Taxes and confirming the recordation of liens, administrative charges and 
assessment charges as necessary pursuant to Title 4, Chapter 4.24 of the 
Oakland Municipal Code, and directing the notice of lien and assessment 
charges to be turned over to the County Tax Collector for collection; or
 
3)     Adopt a Resolution continuing hearing on reports of the Interim City 
Manager on the Delinquent Transient Occupancy Taxes and confirming the 
recordation of liens, administrative charges and assessment charges as 
necessary pursuant to Title 4, Chapter 4.24 of the Oakland Municipal Code
Subject:     Sewer Service Charge Increase Public Hearing
From:          Public Works Agency
Recommendation:  Conduct a Public Hearing and upon conclusion approve the 
Introduction (First Readingof an Ordinance amending Chapter 13 of the 
Oakland Municipal Code (Section 13.04.020increasing the sewer service 
charge and providing for annual increases of eleven percent through January 1
2009 and increases based on the Consumer Price Index thereafter
18
10.15CC 9-30-03.pdf,
12540 CMS.pdf
Attachments:
(Final Passage [Second Reading] has been scheduled for September 30, 2003)
Subject:     Tree Removal Appeal Lot 2006-Moore Drive Public Hearing
From:          Office of Parks and Recreation
Recommendation:  Conduct a Public Hearing and upon conclusion adopt a 
Resolution denying the appeal filed by Ken Paskow and Sheryl Klein against 
the decision of the Director of the Office of Parks and Recreation approving the 
issuance of tree removal permit DR03-068 (Lot 2006, Moore Drive)
19
Subject:  Tree Removal Appeal 5812 Ayala Avenue Public Hearing
From:          Office of Parks and Recreation
Recommendation:  Conduct a Public Hearing and upon conclusion adopt a 
Resolution denying the appeal filed by John Wagers against the decision of the 
Director of the Office of Parks and Recreation approving the issuance of tree 
removal permit DR03-067 (5812 Ayala Avenue)
20
(Items 19 and 20 were withdrawn with no new date at the September 112003, Rules 
and Legislation Committee)
ACTION ON NON-CONSENT ITEMS:
Subject:     Education Partnership Committee Meetings
From:          Councilmember Chang
RecommendationApprove a report recommending to hold in abeyance future 
meetings of the Education Partnership Committee
21
RecommendationThe July 172003, Rules and Legislation Committee approved 
recommendation; Ayes.
 
(This item was withdrawn and rescheduled from the July 292003, City Council meeting 
as a non-consent item)
Subject:          CDBG District Boundaries Adjustments
From:          Community and Economic Development Agency
Recommendation:  Adopt a Resolution to amend Resolution No76276 C.M.S
to extend the term of elected Community Development District Board and 
Citizens Advisory Committee members to two-years; and to realign Community 
Development District boundaries based upon the new low and moderate 
income block group determinations from the 2000 Census data and the 
redistricting of City Council District boundaries
-
22
21 9-30-03.pdf,
78102 CMS.pdf
Attachments:
(This item was withdrawn at the September 112003, Rules and Legislation Committee 
and rescheduled for the September 302003 City Council meeting)
Subject:     Downtown Tenant Improvement Program
From:          Community and Economic Development Agency
RecommendationAdopt an Agency Resolution adopting the Downtown 
Tenant Improvement Program participation criteria to provide matching grants 
to targeted retail, restaurants, arts and entertainment catalyst projects
23 ORA
2003-69 CMS .pdf
Attachments:
RecommendationThe July 222003, Community and Economic Development 
Committee approved recommendation; Ayes.
 
(This item was rescheduled from the July 292003, City Council meeting as a non-
consent item)
Subject:     Establishing Prohibitions on False Endorsements in Campaign 
Literature
From:          Public Ethics Commission
RecommendationApprove the Introduction (First Readingof an Ordinance 
establishing prohibitions on false endorsements in campaign literature
24
10.16CC 9-30-03.pdf,
12536 CMS.pdf
Attachments:
approved recommendation; Ayes.
 
(Final Passage [Second Readinghas been scheduled for September 302003)
Subject:          Fenton's Creamery
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution denying the appeal of EFelizardo and 
upholding the Planning Commission decision to approve the Design Review 
and variances for the restoration and rehabilitation of Fenton's Creamery  at 
4226 Piedmont Avenue and further directing the Planning Commission to 
review all aspects of Fenton's current facility and to make appropriate 
determinations concerning conformity with the applicable provisions of the 
Zoning Code pertaining to legal non-conforming uses
25
78059 CMS.pdf
Attachments:
Recommendation:  The July 292003 City Council meeting directed staff to prepare the 
above resolution; Ayes.
Subject:     Opposition to Proposition 54
From:          Vice Mayor Nadel and Councilmember Wan
Recommendation:  Adopt a Resolution of the Oakland City Council declaring 
its opposition to Proposition 54, the initiative /constitutional amendment 
prohibiting the collection and use of information about race, ethnicity, color or 
national origin by state and local governments, public universities, and school 
districts.
26
78060 CMS.pdf
Attachments:
Time Sensitive:  This item was forwarded directly to the Council agenda due to its time-
sensitive nature and in accordance with the City Council Rules and Procedures, Rule 
23
Subject:     Safe Routes to School Second Cycle Project
From:     Public Works Agency
Recommendation:  Adopt a Resolution authorizing the City Manager to award 
a construction contract in an amount not to exceed $370,000.00 to the lowest 
responsive bidder for the Safe Routes to School Second Cycle Project (City 
Project NoG219210, Federal Project NoSTPLHSR-5012(063)), without 
return to Council"
27
78061 CMS.pdf
Attachments:
Subject:          Installations of Stop Signs 
From:          Public Works Agency
Recommendation:  Adopt a Resolution approving the installation of stop signs 
on Bancroft and 77th Avenue
28
78062 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Central City East Redevelopment Project Area Committee (PAC)
From:     Community and Economic Development Agency
Recommendation:  Adopt a Resolution amending the procedure of formation 
for the Central City East Redevelopment Project Area Committee to replace 
the Melrose High Hopes Neighborhood Crime Prevention Council with the 
Yorkshire Neighborhood Association
29
Subject:     Port of Oakland's Conflict of Interest Code
From:          Office of the City Attorney
Recommendation:  Adopt a Resolution approving a Conflict of Interest Code 
30
for designated employees of the Port of Oakland
78064 CMS.pdf
Attachments:
Subject:     Advancing California's Emerging Technologies (ACET)
From:          Community and Economic Development Agency
Recommendation:  Adopt an Agency Resolution authorizing an owner 
participation agreement with Advancing California's Emerging Technologies (
ACETfor the development of a high-technology business incubator facility in 
the Coliseum Project Area, and the contribution of $1,610,000 in Agency funds 
to the project
31 ORA
(This item was withdrawn with no new date at the September 112003, Rules and 
Legislation Committee)
Continuation of Open Forum
ADJOURNMENT OF COUNCIL SESSION
(Meeting shall conclude no later than 10:30 p.m., unless extended by Majority Vote of the 
Council)